
Margaret Howell Crosthwait

( = Descendancy chart to this point,
= Expand,
= Collapse)
- 1 Margaret Howell Crosthwait [1] b. Abt 1621 d. Abt 1654
John Edward Boyson b. 1620 d. 29 Sep 1684
- 2 Bridget Boyson [1.1]
b. Abt 1646 d. 9 May 1722
Anthony Whitlock b. 1645 d. Aft 1696
- 3 Anne Whitlock [1.1.1]
b. 27 Dec 1695 d. Mar 1774
Thomas Chapman b. 3 Dec 1680 d. 1766
- 4 Jonathan Chapman [1.1.1.1]
b. 24 Mar 1733 d. 1785
Sarah Charge b. 27 Jan 1733 d. 1833
- 5 John Chapman [1.1.1.1.1]
b. 1761
Jane Bunce b. 1763
- 6 William Chapman [1.1.1.1.1.1]
b. 1792 d. 1850
Elizabeth Lowin b. Abt 1791 d. 1850
- 7 Mary Chapman, DA [1.1.1.1.1.1.1]
b. May 1810 d. Abt 1853
John Burton b. 9 Nov 1808 d. 16 Apr 1887
- 8 Rhoda Burton [1.1.1.1.1.1.1.1]
b. Jul 1850 d. Jun 1920
Robert John Marshall b. Abt 1846 d. Oct 1928
- 9 Joseph Marshall [1.1.1.1.1.1.1.1.1]
b. 1874 d. Yes, date unknown
- 9 Percy Marshall [1.1.1.1.1.1.1.1.2]
b. 1877 d. Yes, date unknown
- 9 Louisa Marshall [1.1.1.1.1.1.1.1.3]
b. 1878 d. Yes, date unknown
- 9 Lillian Marshall [1.1.1.1.1.1.1.1.4]
b. 1880 d. Yes, date unknown
- 9 Herbert Marshall [1.1.1.1.1.1.1.1.5]
b. 1884 d. Yes, date unknown
- 10 Gladys Florence Marshall [1.1.1.1.1.1.1.1.5.1]
b. 1907
- 11 Colin Joseph Hilton Ash [1.1.1.1.1.1.1.1.5.1.1]
b. 2 Aug 1931 d. Oct 1993
- 11 Colin Joseph Hilton Ash [1.1.1.1.1.1.1.1.5.1.1]
- 10 Gladys Florence Marshall [1.1.1.1.1.1.1.1.5.1]
- 9 Daisy Marshall [1.1.1.1.1.1.1.1.6]
b. 1885 d. Yes, date unknown
- 9 Isabella Maud Mary Marshall [1.1.1.1.1.1.1.1.7]
b. 23 Jun 1886 d. 20 Jan 1977
Thomas Nathaniel Fowler b. 6 Mar 1885 d. 9 Feb 1943
- 10 Winifred Dora Fowler [1.1.1.1.1.1.1.1.7.1]
b. 16 Jun 1910 d. Mar 1921
- 10 Mary Evans Fowler [1.1.1.1.1.1.1.1.7.2]
b. 24 Dec 1911 d. Oct 1997
Albert Edward Bayliss b. 3 Sep 1910 d. 11 Jan 1977
- 11 Ronald Bayliss [1.1.1.1.1.1.1.1.7.2.1]
b. 5 Apr 1940 d. 2022
- 11 Peter Bayliss [1.1.1.1.1.1.1.1.7.2.2]
b. 14 Sep 1941 d. 22 Dec 2020
G.M. Kenzie
- 12 R.M. Bayliss [1.1.1.1.1.1.1.1.7.2.2.1]
[ =>]
- 12 J.R. Bayliss [1.1.1.1.1.1.1.1.7.2.2.2]
[ =>]
- 12 R.M. Bayliss [1.1.1.1.1.1.1.1.7.2.2.1]
- 11 Wendy Bayliss [1.1.1.1.1.1.1.1.7.2.3]
b. 14 Sep 1941 d. 25 Oct 2016
- 11 Susan Bayliss [1.1.1.1.1.1.1.1.7.2.4]
b. Abt 1946 d. Abt 1948
- 11 L.M. Bayliss [1.1.1.1.1.1.1.1.7.2.5]
A.M. Goodier
- 12 E.J. Goodier [1.1.1.1.1.1.1.1.7.2.5.1]
- 12 H. Goodier [1.1.1.1.1.1.1.1.7.2.5.2]
- 12 E.J. Goodier [1.1.1.1.1.1.1.1.7.2.5.1]
W. Robinson
- 12 F. Robinson [1.1.1.1.1.1.1.1.7.2.5.3]
- 12 F. Robinson [1.1.1.1.1.1.1.1.7.2.5.3]
- 11 Ronald Bayliss [1.1.1.1.1.1.1.1.7.2.1]
- 10 Thomas Fowler [1.1.1.1.1.1.1.1.7.3]
b. 1915 d. Mar 1915
- 10 Isobel Fowler [1.1.1.1.1.1.1.1.7.4]
b. 31 Mar 1916 d. 14 Jan 1995
William Albert Holding b. 6 Jun 1915 d. 17 May 1975
- 11 E.A. Holding [1.1.1.1.1.1.1.1.7.4.1]
- 11 Peter William Holding [1.1.1.1.1.1.1.1.7.4.2]
b. Jan 1945 d. 1 Mar 2018
- 11 E.A. Holding [1.1.1.1.1.1.1.1.7.4.1]
- 10 Joan R Fowler [1.1.1.1.1.1.1.1.7.5]
b. 1918 d. 1919
- 10 Lionel Thomas Fowler [1.1.1.1.1.1.1.1.7.6]
b. 6 Dec 1919 d. Dec 2012
- + Winifred A Bill b. 22 Aug 1926 d. 7 Dec 2018
- + Winifred A Bill b. 22 Aug 1926 d. 7 Dec 2018
- 10 Thomas Fowler [1.1.1.1.1.1.1.1.7.7]
b. 1921 d. 1921
- 10 Barry Gordon Fowler [1.1.1.1.1.1.1.1.7.8]
b. 5 Aug 1924 d. 13 Jan 2008
- 10 June Fowler [1.1.1.1.1.1.1.1.7.9]
b. Apr 1927 d. May 2020
Stanley George Jacques b. 18 Jan 1926 d. 22 Jan 1972
- 11 S. Jacques [1.1.1.1.1.1.1.1.7.9.1]
- 11 A. Jacques [1.1.1.1.1.1.1.1.7.9.2]
- 11 S. Jacques [1.1.1.1.1.1.1.1.7.9.1]
- 10 Winifred Dora Fowler [1.1.1.1.1.1.1.1.7.1]
- 9 Dorothy Marshall [1.1.1.1.1.1.1.1.8]
b. 1888 d. Yes, date unknown
- 9 Ernest Marshall [1.1.1.1.1.1.1.1.9]
b. 1890 d. Yes, date unknown
- 9 Joseph Marshall [1.1.1.1.1.1.1.1.1]
- 8 Rhoda Burton [1.1.1.1.1.1.1.1]
- 7 Mary Chapman, DA [1.1.1.1.1.1.1]
- 6 William Chapman [1.1.1.1.1.1]
- 5 John Chapman [1.1.1.1.1]
- 4 Jonathan Chapman [1.1.1.1]
- 3 Anne Whitlock [1.1.1]
- 2 Bridget Boyson [1.1]